Dealer List
Total: 14,301   Dealer: State:    OR    Zipcode:  Range:

  State City Name     Cars
1951. CT  New Milford  Faustos Auto Body and Repairs LLC  Website Google Map 22 View 
1952. CT  Newington  ABC Auto LLC  Google Map 7 View 
1953. CT  Newington  Wholesale Motorcars LLC  Website Google Map 10 View 
1954. CT  North Branford  CarHavn  Google Map 7 View 
1955. CT  North Branford  Lee J's Auto Sales  Website Google Map 13 View 
1956. CT  North Branford  LeeJ's Auto Sales & Service  Website Google Map 15 View 
1957. CT  North Branford  Route 80 Motors  Website Google Map 5 View 
1958. CT  North Haven  Executive Volkswagen Of North Haven  Website Google Map 111 View 
1959. CT  Norwalk  Black Bridge Motors, LLC  Website Google Map 3 View 
1960. CT  Norwich  MACARA Vehicle Services, Inc  Website Google Map 13 View 
1961. CT  Norwich  ROSE CITY AUTO SALES AND SERVICE LLC  Google Map 17 View 
1962. CT  Old Saybrook  Coastal Performance LLC  Website Google Map 8 View 
1963. CT  Old Saybrook  Grossman Chevrolet Nissan  Google Map 209 View 
1964. CT  Old Saybrook  Saybrook Auto Barn  Website Google Map 27 View 
1965. CT  Old Saybrook  Tapia Auto Care LLC  Google Map 7 View 
1966. CT  Online only  CEO DADDY AUTO  Website Google Map 193 View 
1967. CT  Oxford  Buonauto Enterprises  Website Google Map 78 View 
1968. CT  Plainfield  JPS Automotive Wholesale and Repair LLC  Website Google Map 17 View 
1969. CT  Plainville  Choice Group LLC Choice Motor Car  Website Google Map 104 View 
1970. CT  Plainville  Farmington Auto Park LLC  Website Google Map 26 View 
1971. CT  Plainville  Gengras Volkswagen  Google Map 111 View 
1972. CT  Plainville  Heritage Auto Works  Website Google Map 116 View 
1973. CT  Plainville  New England Auto Sales LLC  Website Google Map 23 View 
1974. CT  Plainville  Wiltse Brothers Garage  Website Google Map 2 View 
1975. CT  Plainville  Xtreme Auto  Website Google Map 37 View 
1976. CT  Plantsville  Auto House of Luxury  Website Google Map 67 View 
1977. CT  Plantsville  L&S Automotive LLC  Website Google Map 67 View 
1978. CT  Portland  F40 Motorsports  Website 28 View 
1979. CT  Portland  Rose Auto LLC  Website Google Map 17 View 
1980. CT  Portland  Velocity Motors LLC  Google Map 28 View 
1981. CT  Prospect  M Sport Motorwerx  Website Google Map 30 View 
1982. CT  Prospect  The Used Car Company LLC  Google Map 3 View 
1983. CT  Putnam  Heritage Valley Ford  Google Map 147 View 
1984. CT  Redding  Wilton Auto Park, LLC  Google Map 15 View 
1985. CT  Ridgefield  FRANKLIN J AUTO SALES LLC  Google Map 15 View 
1986. CT  Ridgefield  Marty Motors Inc  Website Google Map 6 View 
1987. CT  Ridgefield  MULTICAR RIDGEFIELD LLC   Google Map 20 View 
1988. CT  Rocky Hill  Silas Deane Auto LLC  Website Google Map 6 View 
1989. CT  Shelton  Center Motorsports LLC  Website Google Map 4 View 
1990. CT  Somers  Four Town Motors LLC  Website Google Map 15 View 
1991. CT  South Windsor  Fancy Rides LLC  Website Google Map 22 View 
1992. CT  South Windsor  Ful Line Auto  Google Map 36 View 
1993. CT  South Windsor  Ful-line Auto LLC  Website Google Map 35 View 
1994. CT  South Windsor  John Fitch Automotive LLC  Website Google Map 6 View 
1995. CT  South Windsor  Mike And Tony Auto Sales, Inc  Website Google Map 119 View 
1996. CT  Southington  Good Guys Auto House  Website Google Map 2 View 
1997. CT  Stamford  Club Auto Credit  Website 74 View 
1998. CT  Stamford  Global Fleet Leasing LLC  Google Map 59 View 
1999. CT  Stamford  Harbor View Auto Sales LLC  Website Google Map 11 View 
2000. CT  Storrs  Eagleville Motors  Website Google Map 19 View 

prev .. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .. Next